Loading...
HomeMy WebLinkAboutCity Council Minutes 02-14-2023Adopted Minutes Page 1 of 4 Regular Meeting of February 14, 2023 Adopted Minutes Regular City Council Meeting February 14, 2023 Mayor Wosje called a Regular Meeting of the Plymouth City Council to order at 7:00 p.m. in the Council  Chambers of City Hall, 3400 Plymouth Boulevard, on February 14, 2023.     COUNCIL PRESENT:  Mayor Wosje, Councilmembers Willis, McGregor, Pointner, Davis, Peterson  (Councilmember Peterson participated via interactive technology per State Statute 13D.02).     COUNCIL ABSENT: Councilmember Gregor.     STAFF PRESENT: City Manager Callister, Deputy City Manager Solano, Public Safety Director Fadden, Fire  Chief Coppa, Public Works Director Thompson, Finance Director Rich, Community and Economic  Development Manager Fernelius, Ice Arena Manager Halverson, Planning & Development Manager  McGuire, Senior Planner Drill, Fire Fighter McDonnell, City Attorney Mattick, and City  Clerk/Administrative Coordinator Gallup.      Plymouth Forum   Chen Zhou, 5660 Comstock Lane N., inquired about support from the City of Plymouth for the Twin  Cities West Metro Asian Fair. Mayor Wosje stated the City staff will work on this.     Dee Solarz, 415 Merrimac Lane N., recommended the City of Plymouth become a Sanctuary City for Life  especially for the Preborn. City Manager Callister stated they will be in contact.    Zina Gutmanis, 15435 Gleason Lake Drive, provided a variety of reasons why the City of Plymouth should  approve the donation of the fire truck to Ukraine.    Tony Kuechle, 15985 55th Avenue N., expressed his concern over traffic and pedestrian safety at the  southwest corner of 55th Avenue and Vicksburg Lane. Public Works Director Thompson explained that  area is up for a speed safety review this year and potential safety improvements next year or the  following year.      Presentations and Public Information Announcements   There were no presentations or public information announcements.       Approval of Agenda   Adopted Minutes Page 2 of 4 Regular Meeting of February 14, 2023 Motion was made by Councilmember Pointner, and seconded by Councilmember Willis, to approve the  agenda. With Mayor Wosje and Councilmembers Willis, McGregor, Pointner, Davis and Peterson voting  in favor, the motion carried.    Consent Agenda   Motion was made by Councilmember Willis, and seconded by Councilmember Pointner, to adopt the  Consent Agenda that included the following items:    (6.1) Council Minutes from Special Meeting of January 21, 2023 and Special Meeting and Regular  Meeting of January 24, 2023.    (6.2) Resolution Approving Disbursements ending February 3, 2023 (Res2023‐043).  (6.3) Resolution Approving Plans and Specifications, and Ordering Advertisement for Bids for the  Chankahda Trail Reconstruction Project – Phase 2 (ST230002) (Res2023‐044), Resolution to Authorize  “No Parking” for the Chankahda Trail Reconstruction Project – Phase 2 (ST230002) (Res2023‐045).  (6.4) Resolution Approving a Variance for Scanlon Inc. for Property Located at 19040 County Road 6  (2022086) (Res2023‐046).    (6.5) Resolution Approving Tobacco License Application of Kareem Inc D/B/A I Mart Stores, 4140  Berkshire Lane North (Res2023‐047).  (6.6) Resolution Designating Consulting Engineer for the 2024 Old Rockford Road Trunk Watermain  Lining Project (WA249005) (Res2023‐048).  (6.7)  Resolution Authorizing the Mayor and City Manager to Execute Amendment No. 2 to the  Development Contract for Hampton Hills South Plateau (2011097‐F) (Res2023‐ 049).  (6.8) Resolution Accepting Utilities for Continual Maintenance for Hollydale 2nd Addition (2022023)  (Res2023‐050).  (6.9) Resolution Approving a Variance for Robert Mueller for Property Located at 17145 9th Ave N  (2022085) (Res2023‐051).  (6.10) Resolution Approving Cooperative Agreement with Hennepin County for the County Road 9 at  Trunk Highway 169 Bridge Replacement (ST200002) (Res2023‐052).  (6.11) Resolution Approving a Site Plan Amendment and Conditional Use Permit for Honeywell  International, Inc. for Property Located at 12001 Highway 55 (2022081) (Res2023‐053).  (6.12) Resolution Approving Waiver of Real Property Declaration Certification for the MCES 2020  Municipal I/I Grant Program (Res2023‐054).   (6.13) Authorize National League of Cities conference travel request.  Adopted Minutes Page 3 of 4 Regular Meeting of February 14, 2023 With Mayor Wosje and Councilmembers Willis, McGregor, Pointner, Davis and Peterson voting in favor,  the motion carried.      Public Hearings   (7.1) Public Hearing on Off‐Sale Intoxicating Liquor License Application of Haskell's, Inc. D/B/A  Haskell's, 4130 Berkshire Lane North, Plymouth    City Clerk/Administrative Coordinator Gallup presented this item and stated the Police Department did  not find any reason to deny the license and property owners within 500 feet have been notified.     Mayor Wosje opened the public hearing.    Mayor Wosje closed the public hearing.    City Attorney Mattick noted roll call is required when a Councilmember is present via interactive  technology.  Motion was made by Councilmember Willis, and seconded by Councilmember Davis, to adopt  Resolution Approving Off‐Sale Intoxicating Liquor License Application of Haskell’s, Inc. D/B/A Haskell’s,  4130 Berkshire Lane North (Res2023‐055). With Mayor Wosje and Councilmembers Willis, McGregor,  Pointner, Davis and Peterson voting in favor, the motion carried.       General Business (8.1) Approve Fire State Aid Allocation Agreement with the Plymouth Fire Relief Association    Deputy City Manager Solano and Firefighter McDonnell presented this item and recommended approval  of a 2‐year agreement with the City of Plymouth and the Fire Relief Association. Firefighter McDonnell  provided background information on the agreement and explained this helps to recruit and retain well  qualified fire personnel and maintain proper retirement benefits. This agreement would allow for a  percentage to be allocated each year instead of a specified dollar amount.      The City Council expressed their thanks and appreciation.    Motion was made by Councilmember Willis, and seconded by Councilmember McGregor, to adopt  Resolution Authorizing a Fire State Aid Allocation Agreement Between the City of Plymouth and the  Plymouth Fire Relief Association (Res2023‐056). With Mayor Wosje and Councilmembers Willis,  McGregor, Pointner, Davis and Peterson voting in favor, the motion carried.      (8.2) Approve Preliminary and Final Plat, Site Plan, and Variances for a "Suite Living" Assisted  Living/Memory Care Home in the West Portion of Property Located at 4325 Zachary Lane (Hampton  Companies, LLC ‐‐ 2022‐080)    Senior Planner Drill presented this item. He provided background information and stated the Planning  Commission and City staff have recommended this project.  Adopted Minutes Page 4 of 4 Regular Meeting of February 14, 2023   In response to questions from the Council, Senior Planner Drill provided the following information:   The project complies with all P‐1 standards and the Planning Commission noted one lot is  slightly under the 2‐acre minimum size requirement but would not be noticeable due to the  amount of open space.   The City will look into a more flexible easement agreement if it ever becomes necessary.   The City will discuss a blanket easement for access to Lot 2 and will look into emergency vehicle  access.   Noted shielding light fixtures have to be within 300 feet of a residence, color temperatures will  be decreased and the lumens and height requirements have been met.    Motion was made by Councilmember Davis, and Seconded by Councilmember Pointner, to adopt  Resolution Approving Preliminary and Final Plat, Site Plan, and Variances for Hampton Companies, LLC  for an Assisted Living/Memory Care Home in the West Portion of 4325 Zachary Lane (2022080)  (Res2023‐057). With Mayor Wosje and Councilmembers Willis, McGregor, Pointner, Davis and Peterson  voting in favor, the motion carried.      Reports and Staff Recommendations   City Manager Callister updated the Council on the Chankahda bonding bill and will continue to reach out  to the Governor’s office for more support.       Adjournment   Mayor Wosje adjourned the regular meeting at 7:43 p.m.             _________________________________________        Jodi Gallup, City Clerk/Administrative Coordinator